Report: Women by first name

         Description: All the women in the database sorted on first name


Matches 6801 to 6900 of 7898

«Prev «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 79» Next»

# Person ID Full Name Title Spouse Name Spouse ID Birth Date Birth Place Marriage Date Marriage Place Death Date Death Place
6801 I19369  LEATHERS, Molly Polly    LANGLEY, Moses  I19354  1774  New Hampshire, USA   4 Nov 1790  New Hampshire, USA      
6802 I6611  DOUCET, Monique        17 Jul 1779  St. Marys Bay, Digby, Nova Scotia, Canada       1844   
6803 I11343  GAUDET, Monique        16 Apr 1772        1816   
6804 I13774  GIROUX, Monique        1679           
6805 I13135  LANDRY, Monique        18 May 1757  Saint-François, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada       16 Aug 1773  Sainte-Marie, La Nouvelle-Beauce, Quebec, Canada  
6806 I13246  LANDRY, Monique        1737           
6807 I7832  MELANSON, Monique        15 Jul 1849  Plympton, Digby, Nova Scotia, Canada       4 Feb 1921  Comeauville, Nova Scotia, Canada  
6808 I6112  AMERINDIAN, MONTAGNAISAMERINDIAN, MONTAGNAIS    LARCHE, PIERRE  I6104  1601  Port Royal, Nova Scotia, Canada       1665   
6809 I7450  O'TOOLE, Mor    MACMURROUGH, Dermot  I7449  1114        1191   
6810 I3929  AYLESWORTH, Mrs Nathaniel    AYLESWORTH, Nathaniel  I3928  1589  England   1608  England   1634  Reading, Middlesex, Massachusetts, USA  
6811 I919  SMITH, Muriel MSMITH, Muriel M    RAYMOND, Adelard Joseph Omar  I1009  17 May 1902  Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada   16 Apr 1922  Lynn, Essex, Massachusetts, USA   24 May 1988  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA  
6812 I919  SMITH, Muriel MSMITH, Muriel M        17 May 1902  Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada       24 May 1988  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA  
6813 I410  ADAMS, NancyADAMS, Nancy    Living  I10570  11 May 1786  Barnstead, Belknap, New Hampshire, USA       Apr 1866  Barnstead, Belknap, New Hampshire, USA  
6814 I2454  FRENCH, NancyFRENCH, Nancy        22 Nov 1807  Tewksbury, Middlesex, Massachusetts, USA       10 Jan 1886  Tewksbury, Middlesex, Massachusetts, USA  
6815 I10572  NORTON, Nancy    ADAMS, Hanson Hoyt  I408      1817  Portsmouth, Rockingham, New Hampshire, USA   6 Dec 1886   
6816 I3882  SHOREY, Nancy        17 Aug 1795  Fayette, Kennebec, Maine, USA       7 Mar 1865  Albion, Kennebec, Maine, USA  
6817 I2926  SHOREY, Nancy Anna        1760  South Berwick, York, Maine, USA          
6818 I1687  DEROCHEMONT, Nancy Elizabeth        29 Jan 1878  Newburyport, Essex, Massachusetts, USA       27 Jun 1878  Newburyport, Essex, Massachusetts, USA  
6819 I15855  CHAISSON, Nanette        1763  Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada       1793   
6820 I11656  CHIASSON, Nanette        1760  Nova Scotia, Canada       13 Apr 1814  Shippagan, Gloucester, New Brunswick, Canada  
6821 I7767  BICKNELL, Naomi        21 Jun 1657  Weymouth, Norfolk, Massachusetts, USA       11 Sep 1719  Weymouth, Norfolk, Massachusetts, USA  
6822 I6581  ARSENAULT, NatalieARSENAULT, Natalie    BERNARD, Joseph  I6542  1738  Queens, Prince Edward Island, Canada   1755  Restigouche, New Brunswick, Canada   20 Jan 1821  Egmont Bay, Prince Edward Island, Canada  
6823 I15117  GEPARD, Nathalie          Quebec, Canada       Bef 1859  Quebec, Canada  
6824 I3850  PROVENCHER, Nathalie        19 Feb 1839  Bécancour, Quebec, Canada          
6825 I1739  FULGHUM, Nell    DEROCHEMONT, Paul L  I1691  24 Aug 1929  Selma, Johnston, North Carolina, USA       19 Nov 1997  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA  
6826 I5415  MELANSON, NellieMELANSON, Nellie        6 Aug 1881  Nova Scotia, Canada          
6827 I14533  MACE, Nellie B        24 Oct 1882  Portsmouth, Rockingham, New Hampshire, USA       18 Sep 1908  Portsmouth, Rockingham, New Hampshire, USA  
6828 I19219  BEDELL, Nellie EBEDELL, Nellie E        1874  Haynesville, Aroostook, Maine, USA       1944   
6829 I15558  ADAMS, Nellie M.        Abt 1876  Massachusetts, USA          
6830 I4342  BURNHAM, Nellie M.BURNHAM, Nellie M.        Abt 1876  New Hampshire, USA       27 Jul 1905   
6831 I1957  WILSON, NellieHelen M    DEROCHEMONT, Irving Storer  I1656  Abt 1869  Charlestown, Suffolk, Massachusetts, USA   Abt 1889       
6832 I3328  FERCH GRUFFYDD, Nest    FITZRICHARD, Osbern  I3327  1059  Rhuddlan, Flintshire, Wales     Rhuddlan, Flintshire, Wales   1152  Richards Castle, Herefordshire, England  
6833 I3333  OSBERN, Nest ferchOSBERN, Nest ferch    NEUFMARCHE, Bernard De  I3325    Hereford, Herefordshire, England   1093  Breconshire, Wales   4 Jan 1163  Brecon, Breconshire, Wales  
6834 I2056  GAMESTER, Nettie        21 Feb 1902  Saint Malbane, Prince Edward Island, Canada       3 Jun 1992  Eliot, York, Maine, USA  
6835 I80  SHOREY, Nettie EllenSHOREY, Nettie Ellen    PATTERSON, Levi Thomas  I10178  30 May 1872  Littleton, Aroostook, Maine, USA   15 Jun 1898  Auburn, Androscoggin County, Maine, USA   1963  Freeport, Cumberland, Maine, USA  
6836 I80  SHOREY, Nettie EllenSHOREY, Nettie Ellen        30 May 1872  Littleton, Aroostook, Maine, USA       1963  Freeport, Cumberland, Maine, USA  
6837 I5050  SHIRLEY, Nicholaia        1386  Wiston, Sussex, England          
6838 I9015  HOWARD, Nicholas        1452  Norfolk, Essex, England       1510  England  
6839 I5718  BELANGER, Nicolas        17 Jan 1672  Charlesbourg, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada       12 Apr 1742  Beauport, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  
6840 I11522  DALAIRE, Nicolas Joseph        1703        1703   
6841 I12451  LOIGNON, Nicolas Joseph        23 Jan 1655  Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada       9 Sep 1661  Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  
6842 I20365  BOUCHER, Nicole        1611           
6843 I18524  DUCHESNE, NicoleDUCHESNE, Nicole    LAPORTE DIT SAINT-GEORGES, Jacques  I18523  3 Sep 1637  Meaux, Seine-et-Marne, Île-de-France, France   3 Sep 1657  Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada   27 Jul 1703  Verchères, Lajemmerais, Quebec, Canada  
6844 I18295  FONTAINE, Nicole        13 déc. 1629  St Nicolas De Lagny, Beauvais, Oise, Picardie, France       1726  Paris, Paris, Île-de-France, France  
6845 I14602  LEGRAND, NicoleLEGRAND, Nicole    NOEL, François  I14601  1648  Paris, Île-de-France, France       5 Oct 1713  Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada  
6846 I13627  PHILIPPEAU, Nicole        Abt 1655  France, Lot-et-Garonne, Aquitaine, France       11 May 1716  Varennes, Lajemmerais, Quebec, Canada  
6847 I13418  PHILIPPEAU PHILIPPE, NicolePHILIPPEAU PHILIPPE, Nicole    GAUTHIER LAROUCHE, Mathurin  I13417  21 Nov 1655  Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France   Bef 28 Jun 1672  Montréal, Montréal (Urban Agglomeration), Quebec, Canada   11 May 1716  Verchères, Lajemmerais, Quebec, Canada  
6848 I11531  SAULNIER, NicoleSAULNIER, Nicole    BROCHU DIT LAFONTAINE, Jean  I11530  1651  St Christophe, Indre, Centre, France       2 Nov 1714  Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada  
6849 I12094  GAREMAN, Nicole-Madeleine        1631  Soissons, Aisne, Picardie, France       10 Apr 1688  Portneuf, Quebec, Canada  
6850 I5607  GOSSARD, NoëlleGOSSARD, Noëlle    BUSSIÈRE, Jacques  I5660  1634  Paris, Île-de-France, France   16 Oct 1671  Sainte-Famille, L'Île-d'Orléans, Quebec, Canada   19 Nov 1684  Montmorency, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  
6851 I3836  GILBERT, Noemi JosephineGILBERT, Noemi Josephine    GORMAN, John David  I15564  6 Apr 1900  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA   29 Aug 1927  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA   1 Apr 1984  Dover, Strafford, New Hampshire, USA  
6852 I1209  TURCOTTE (TURCOT), Obéline        22 Jul 1825  Rivière-du-Loup, Quebec, Canada       29 Jul 1886  Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada  
6853 I7494  VERDUN, Oda of    LAMBERT, II  I10364  990        1062  Leuven, Vlaams-Brabant, Belgium  
6854 I7494  VERDUN, Oda of        990        1062  Leuven, Vlaams-Brabant, Belgium  
6855 I18765  PARROW, OdelePARROW, Odele        6 Jun 1882  Cass, North Dakota, USA       5 Aug 1912  Havana, Sargent, North Dakota, USA  
6856 I1002  BELIVEAU, Odile        1839  Quebec City, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada          
6857 I1096  DUMAS, OdileDUMAS, Odile    LÉTOURNEAU, Ignace Ozéas Phidélème  I18759  7 Apr 1855  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada   29 Déc 1873  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada   19 May 1935  Havana, Sargent, North Dakota, USA  
6858 I1096  DUMAS, OdileDUMAS, Odile    GALLAGHER, Charles E.  I18763  7 Apr 1855  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada   3 Nov 1909  Britton, Marshall, South Dakota, USA   19 May 1935  Havana, Sargent, North Dakota, USA  
6859 I1096  DUMAS, OdileDUMAS, Odile    PARROW (PERRAULT), Edward  I18764  7 Apr 1855  Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Montmagny, Quebec, Canada   5 Nov 1877  Kankakee, Kankakee, Illinois, USA   19 May 1935  Havana, Sargent, North Dakota, USA  
6860 I1323  VERMETTE, OdileVERMETTE, Odile        14 Sep 1896  Salmon Falls, Strafford, New Hampshire, USA       21 Oct 1950  Lewiston, Androscoggin, Maine, USA  
6861 I10937  LUSSIER, Odile Eloise?        1837  Varennes, Lajemmerais, Quebec, Canada          
6862 I17944  LEBLOND, OlivaLEBLOND, Oliva        10 Sep 1903  Canada       7 Jan 1920  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA  
6863 I3520  AYERS, OliveAYERS, Olive    HODGDON, Phineas  I3543  1735  Greenland, Rockingham, New Hampshire, USA   2 Jan 1758  Greenland, Rockingham, New Hampshire, USA   12 Nov 1813  Greenland, Rockingham, New Hampshire, USA  
6864 I16708  BICKFORD, OliveBICKFORD, Olive    ELLIS, John W. (Joseph)  I16727  1795  New Hampshire, USA   12 May 1816  New Durham, Strafford, New Hampshire, USA   2 Oct 1865  Alton, Belknap, New Hampshire, USA  
6865 I20124  COLBATH, Olive        1784  Farmington, Strafford, New Hampshire, USA       14 Feb 1816  Farmington, Strafford, New Hampshire, USA  
6866 I3522  CORSON, Olive        Aft 1805  Lebanon, York, Maine, USA          
6867 I11034  DOYON, Olive        26 Dec 1899  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA       6 Oct 1955   
6868 I9047  GOODWIN, Olive        1697  Kittery, York, Maine, USA       12 May 1772   
6869 I461  HARMAN, Olive    ATWOOD, Nicholas  I788  10 May 1548  Sanderstead, Surrey, England   30 Jan 1570  Westminster, Middlesex, England   1603  Elstree Church, Herefordshire, England  
6870 I4960  HODGDON, Olive    ADAMS, Nathaniel  I4959  1771           
6871 I16378  HOOPER, Olive        4 Aug 1728  Berwick, York, Maine, USA         Berwick, York, Maine, USA  
6872 I2049  LEIGHTON, Olive    COLBATH, James  I2048  1720  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA   1738  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA   1800  Middleton, Strafford, New Hampshire, USA  
6873 I2049  LEIGHTON, Olive        1720  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA   1738  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA   1800  Middleton, Strafford, New Hampshire, USA  
6874 I3028  LIBBY, Olive        Abt 1768  Berwick, York, Maine, USA          
6875 I1370  SHOREY, Olive        13 Nov 1832  Monticello, Aroostook, Maine, USA       31 May 1909  Dexter, Penobscot County, Maine, USA  
6876 I7943  TRUFANT, Olive        1791  Bowdoin, Lincoln, Maine, USA          
6877 I9460  WALKER, Olive        20 Jul 1728  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA       1733  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA  
6878 I20173  WALKER, Olive        29 Feb 1756  Newington, Rockingham, New Hampshire, USA          
6879 I19021  WHITCOMB, Olive        24 Apr 1761  Templeton, Worcester, Massachusetts, USA       5 Feb 1807  Massachusetts, USA  
6880 I3894  SHOREY, Olive Alice        22 Mar 1810  Lebanon, York, Maine, USA       28 Apr 1885  Lebanon, York, Maine, USA  
6881 I19553  MALLET, Olive ColletMALLET, Olive Collet    WOODMAN, Edward  I19552  8 Feb 1579  Corsham, Wiltshire, England   30 Jun 1600  Corsham, Wiltshire, England   5 Jul 1611  Corsham, Wiltshire, England  
6882 I1362  HOYT, Olive FolsomHOYT, Olive Folsom    DEROCHEMONT, Herbert Stanley  I414  Abt 1855  Greenland, Rockingham, New Hampshire, USA   29 Apr 1877  Greenland, Rockingham, New Hampshire, USA      
6883 I3831  BLACKMAN, Olive H.    SHOREY, Edmond Sr.  I1390  1790    11 Apr 1812  Albion, Kennebec, Maine, USA   4 Jan 1826  Albion, Kennebec, Maine, USA  
6884 I19233  WHITNEY, Olive Jennie        7 Sep 1847  Brunswick, Cumberland, Maine, USA          
6885 I17984  BÉLIVEAU, Olivine        19 Oct 1857  Saint-Sophie, Canada       8 Jan 1941  Franklin, Merrimack, New Hampshire, USA  
6886 I8008  FORTIER, OlivineFORTIER, Olivine    LETOURNEAU, Emile W  I15433  6 Jul 1895  Saint-Fortunat, Les Appalaches, Quebec, Canada   9 Jul 1923  Fall River, Bristol, Massachusetts, USA   1949  Fall River, Bristol, Massachusetts, USA  
6887 I694  LEBLOND, OlivineLEBLOND, Olivine    GILBERT, Edward  I166  27 Jan 1888  Canada   Bef 1916  Somersworth, Strafford, New Hampshire, USA   25 Jan 1950  Concord, Merrimack, New Hampshire, USA  
6888 I694  LEBLOND, OlivineLEBLOND, Olivine    DIONNE, Alfred  I4826  27 Jan 1888  Canada   Aft 1926    25 Jan 1950  Concord, Merrimack, New Hampshire, USA  
6889 I3773  PROVENCHER, OraPROVENCHER, Ora        Abt 1864  Canada          
6890 I14419  LEVESQUE, Osithe        26 Apr 1813  Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada          
6891 I14445  SIROIS DITE DUPLESSIS, Osithe    LEVESQUE, Pierre  I14412  24 Nov 1807  Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada   20 Oct 1829  Rivière-Ouelle, Kamouraska, Quebec, Canada   21 Oct 1878  Mont-Carmel, Kamouraska, Quebec, Canada  
6892 I20094  GOUSHALL, Oswalda    JOCELYN, William  I20093  Abt 1110  England          
6893 I17662  OUTCHIBAHANOUKOUEOU, OuéouOUTCHIBAHANOUKOUEOU, Ouéou    MANITOUABEWICH, Roch  I17661  Abt 1600  Canada       Abt 1649  Quebec, Canada  
6894 I1005  BELIVEAU, Parmelie        1835  Quebec City, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada       1889   
6895 I10943  LUSSIER, Parmelie        Abt 1863  Quebec City, Quebec (Urban Agglomeration), Quebec, Canada       16 Feb 1906  Millis, Norfolk, Massachusetts, USA  
6896 I9107  ABBOTT, Patience    Living  I17002  1685  Kittery, York, Maine, USA   1705    Mar 1756  Berwick, York, Maine, USA  
6897 I9308  AUSTIN, Patience        1688  York, York, Maine, USA       3 Nov 1735  York, York, Maine, USA  
6898 I8030  BRAGDON, Patience        17 Apr 1678  York, York, Maine, USA       13 Nov 1753  York, York, Maine, USA  
6899 I8047  BUNKER, Patience        1716  Dover, Strafford, New Hampshire, USA       1770  Dover, Strafford, New Hampshire, USA  
6900 I8467  CHADBOURNE, PatienceCHADBOURNE, Patience    SPENCER, Thomas  I8466  8 Nov 1612  Tamworth, Staffordshire, England   Aft 1629    7 Nov 1683  South Berwick, York, Maine, USA  


«Prev «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 79» Next»

Go to Top